Loading...
2008-11-05  B OARD OF SUPERVISORS T E N T A  T I V E NOVEMBER 5, 2008 9:00 A.M., LAN E AU DITORIU M C OUNTY OFFICE BUILDIN G     1.         Call to Order. 2.         Pledge of Allegiance. 3.         Moment of Silence. 4.         Recognitions:             a.         Miller School Fire Fighting Efforts.             b.         Digital Government Aw ard.             c .         Bob W illingham, County  Assessor. 5.         From the Board:  Matters Not Lis ted on the Agenda. 6.         From the Public:  Matters Not Listed for Public Hearing on the Agenda. 7.         Consent Agenda (on next sheet).   10:00 a.m. – A ction Items: 8.         Jail Inmate Reentry Initiative Program, Ronald Matthews, Superintendent, Charlottesville­Albemarle Regional Jail. 9.         Request to Seek Enabling Legislation to Establis h a Regional Transit Authority in the Charlottesville­ Albemarle Area.   10:30 a.m. – Information/Presentation Items: 10.        Region Ten Community Services Board, Robert Johnson, Ex ecutive Direc tor. 11.        Historic Pres erv ation C ommittee U pdate.   11:00 a.m. – Public H earings: 12.        Abandonment of right­of­way in Section III of Brookwood Subdivision.  Consider abandonment of 50­ foot right­of­way under Virginia C ode § 33.1­157 et seq., dedic ated to the County on the subdiv ision plat of Section III of the Brookwood subdivision, recorded in the Clerk’s Office of the C ircuit Court of the County of Albemarle at D eed Book 601, page 311.  The right­of­way intended to be vacated is not in the s tate­ maintained sy stem of secondary highw ays and is located along the forested boundary between the residential properties known as 5553 and 5559 Brookwood Road in the Crozet area of the W hite Hall Magisterial Dis tric t. 13.        FY 2009 Budget Amendment.   14.        Closed Meeting. 15.        Certify Closed Meeting. 16.        Boards and Commissions:             a.         Vacancies /Appointments.   2:00 p.m. – Transportation Matters 17.        a.         VDOT Monthly Report.             b.         Transportation Matters not Listed on the Agenda.   2:30 p.m. ­ W ork Sessions: 18.        3:00 p.m. – 3:30 p.m. – Economic D evelopment Policy Comprehensive Plan Amendment. 19.        3:45 p.m. – Five Year Financ ial Plan.   21.        From the Board:  Matters Not Lis ted on the Agenda.   22.        Adjourn to November 7, 2008, 1:00 p.m., Room 241.       C O N S E N T   A G E N D A     FOR APPR OVAL:   7.1        Approval of Minutes:  September 5, September 28, October 11 and October 19, 2007; and March 10, 2008.   7.2        Fiscal Year 2009 C ounty of Albemarle & State Health Department Local Government Agreement.   7.3        Route 640 (Turk ey Sag Road) – Abandonment and Addition of Road Segments.   7.4        Abandonment and Addition of Road Segments  ­ Earlysville R oad (R oute 743) and Dickerson Road (Route 606) and Rio Mills Road (Route 643).   7.5        Acquisition of Garnett and Other FY 2007­08 C lass ACE Eas ements.   7.6        Set public hearing to consider proposed ordinance to amend C ounty Code Chapter 9, Motor Vehicles and Traffic , Article I, In General, and Artic le IV, C ounty              Vehicle Licenses to eliminate the County  vehicle decal requirement.   7.7        Petty Cash Res olution to amend Petty Cash Fund for Holly mead and Monticello Fire Stations.   7.8        Leahs Lane Road Name Change to R onins W ay .   7.9        Reas Creek Drive Road Name Change to Golf Drive.   7.10      Resolution of the Economic D evelopment Authority of Albemarle C ounty, Virginia, authorizing the is suance of up to $23,100,000 in revenue bonds for The Univ ers ity of Virginia Health Services Foundation.    7.11      Historic Croz et Streetscape Enhancement Project – Phase 2, Authorize County  Executive to sign revised Dominion Power Agreement for relation of            utility lines  on Crozet Avenue.   7.12      Resolution to ac cept roads in Mosby Mountain Subdivision into the State Secondary System of Highw ays .   7.13      FY 2008 End­of­Year Preliminary Financial R eport.   7.14      Cancel Board of Supervisors’ D ecember 10, 2008 meeting.   FOR IN FORMATION:   7.15      Board­to­Board Monthly Communications Report from School Board, November, 2008.   7.16      Copy of application of Virginia Electric and Power Company: Notification to the Commission of Election to Abandon the Company’s Bidding Program and Application to Revis e its C ogeneration Tariff Pursuant to PURPA Sec tion 210, Case No. PUE­2008­00078. (on file in C lerk's office)   7.17      Copy of letter dated October 16, 2008, from J ohn Shepherd, Manager of Zoning Administration, to D onna R . DeLoria, Esq., Payne & H odous, LLP, re:  OFFICIAL DETERMINATION OF D EVELOPMENT RIGHTS – Tax Map 123, Parcels 4 & 7, Scottsville Magisterial District (property of Murcielago, LLC ) Section 10.3.1.   7.18      Copy of letter dated October 22, 2008, from the Honorable Governor Timothy M. Kaine, to the H onorable Ed Sc hafer, Secretary of Agriculture, re:  designation of localities  as  disaster areas  due to drought and heat for crop year 2008.        Ret urn t o Top of   Agenda Ret urn t o Board of  Superv isors Home P age Ret urn t o Count y  Home Page