Loading...
2011-12-07  B OARD OF SUPERVISORS T E N T A  T I V E DECEMBER 7, 2011 9:00 A.M., AUD ITORIUM C OUNTY OFFICE BUILDIN G     1.         Call to Order. 2.         Pledge of Allegiance. 3.         Moment of Silence. 4.         Adoption of Final Agenda. 5.         Recognitions. 6.          From the Public:  Matters Not Lis ted for Public  Hearing on the Agenda. 7.          C onsent Agenda (on next sheet).   10:00 a.m. ­ Public H earings: 8.         AFD­2011­00006. Addition of the following parc el(s) to the Sugar Hollow Agricultural and Forestal D istrict (Albemarle County Code § 3­226): Tax map 26, parcel 10G.   The parc el proposed for addition is approximately  8.56 acres in size and located on Carrs Ridge Rd approximately 0.5 miles northwest of its intersection w ith Sugar Ridge R oad (R oute 674).  The Albemarle County Agricultural and Forestal Advisory C ommittee recommended approval of this addition. 9.         AFD­2011­00007. Creation of the Glen Oaks A gricultural and Forestal District.  The parcels that would c ompose the proposed District are Tax Map 94, Parcels 15A1 and 15A2.  The proposed D istrict would be approximately  257.17 acres in s ize and located on an un­named private road approximately 0.75 miles beyond the end of Running D eer Dr (R oute 808).  The Albemarle County Agricultural and Forestal Advisory C ommittee recommended approval of this district.     10.       AFD­2011­00008. Addition of the follow ing parcel(s) to the Keswick A gricultural and Forestal District (Albemarle County  Code § 3­219): Tax map 81, parcels 74 and 79.  The parcel proposed for addition are approximately  57.27 acres in siz e and located on Barn Field Dr, approximately 1 mile from its  intersection w ith Clarks Trac t R d (Route 648).  The Albemarle County Agric ultural and Forestal Advisory  Committee recommended approval of this addition.    11.       AFD­2011­00009. Addition of the follow ing parcel to the Blue Run Agricultural and Forestal D istrict (Albemarle County  Code § 3­208): Tax map 22, parcel 10. The parcel proposed for addition is approximately 28.765 acres in size and is located on Burnley  Station Road, approximately  3.3 miles west of its intersection w ith Stony Point Road (Route 20). The Albemarle County Agricultural and Forestal Advisory C ommittee recommended denial of this addition. 12.       AFD­2011­00010. Addition of the follow ing parcel to the Bucks Elbow Mountain A gricultural and Forestal D istrict (Albemarle County Code § 3­209.5): Tax map 39, parcel 1D.  The parc el proposed for addition is approximately  11 acres in siz e and located on Bucks Elbow Mtn R d approx imately 1.5 miles northeast of its intersection w ith Jarmans Gap R d (Route 611).  The Albemarle County Agric ultural and Forestal Advisory C ommittee recommended approval of this addition.   10:30 a.m. ­ A ction Items: 13.       10:30 a.m. ­ WPO­2007­00104 (H yland Ridge Subdivision) – R equest to extend deadline for installing permanent vegetation. 14.       10:45 a.m. ­ Meadow Creek Parkway R esolution. 15.       11:05 a.m. ­ Fire Services Agreement Between the City of C harlottesville and Albemarle County. 16.       11:25 a.m. – Wireless Policy /Regulations Update.   17.       Closed Meeting. 18.       Certify Closed Meeting. 19.       Boards and C ommissions:  Vacancies/Appointments.   1:30 p.m. – Presentations: 20.       1:45 p.m. – JAU NT:             a.         Presentation of 2011 Annual Report.             b.         FY12 Supplemental Funding Request. 21.       2:15 p.m. ­ Cate Wyatt, President of the Journey Through Hallowed Ground.   22.       2:30 p.m. ­ Work Session:  Five Year Financ ial Plan.     23.       From the Board:  Matters Not Listed on the Agenda.   24.       Adjourn to December 14, 2011, 4:00 p.m., R oom 241.       CON SENT AGEND A     FOR APPR OVAL: 7.1        Approval of Minutes:  March 9, September 7 and September 14, 2011.   7.2       FY 2012 Budget Amendment and Appropriations.   7.3       WPO­2008­00079, WPO­2010­00052 and W PO­2010­00066 (Moores Creek  Treatment Plant); W PO­2008­ 00080 (Pavilions  at Pantops Phas e 3) – Request to extend deadline for installing permanent vegetation.   7.4       Fis cal Year 2012 County of Albemarle & State Health Department Local Government Agreement.   FOR IN FORMATION:   7.5       Board­to­Board ­ Albemarle County School Board Monthly Report for December 2011.   7.6       FY12 First Quarter Financial R eport.   7.7       VDoT C ulpeper D istrict – Albemarle C ounty Monthly Report for December 2011.   7.8       Copy of letter dated November 22, 2011, from Ronald L. Higgins, Chief of Zoning/Deputy Zoning Administrator, to Dr. Joseph W. May, re:  OFFIC IAL DETERMINA TION OF PA RCELS AND D EVELOPMENT RIGHTS – Tax Map 65, Parcel 14A (property of Joseph W. May) – Rivanna Magisterial District.   7.9       Copy of letter dated November 22, 2011, from Ronald L. Higgins, Chief of Zoning/Deputy Zoning Administrator, to Brian S. Ray, re:  OFFICIAL D ETER MINA TION OF PARCELS A ND DEVELOPMENT R IGH TS – Tax Map 88, Parcel 5 & 42A (property of David H . B ass & Nancy K . B ass) – Samuel Miller Magisterial District.   7.10       Copy of letter dated November 22, 2011, from R onald L. Higgins, Chief of Zoning/D eputy  Zoning Administrator, to Virginia Land Trust, c/o Greg Baldw in, re:  OFFICIAL DETER MINATION OF PAR CEL OF RECORD  – Tax Map 79, Parcel 23 (portion) (property of Virginia Land Trust) – Scottsville Magisterial District.       Ret urn t o Top of   Agenda Ret urn t o Board of  Superv isors Home P age Ret urn t o Count y  Home Page