Loading...
2015-01-07  B OARD OF SUPERVISORS T E N T A  T I V E JANU ARY 7, 2015 C OUNTY OFFICE BUILDIN G 1:00 P.M. – AUD ITOR IUM     1.         Call to Order. 2.         Pledge of Allegiance. 3.         Moment of Silence.   Annual Organization 4.          Election of Chairman. 5.          Election of Vice­Chairman. 6.          Appointment of C lerk and Senior D eputy Clerk. 7.         Board 2015 Calendar: a.         Set Meeting Times, Dates and Places for Calendar Year 2015. b.         Set D ates for Hearing Zoning Text Amendments Requested by Citizens. 8.         Adoption of Rules of Procedures /Policies. 9.         Adoption of Final Agenda. 10.       Brief Announcements by Board Members. 11.       Recognitions:             a.         Scott Keim – Executive Fire Officer. 12.        From the Public:  Matters Not Listed for Public Hearing on the Agenda. 13.        Consent Agenda.               2:00 p.m. ­ W ork Sessions: 14.       Water Resources Program – Level of Service. (Doug W alker, Deputy County  Executive)   3:00 p.m. ­ Presentation: 15.       Board­to­Board, School Board C hairman. (Ned Gallaway) 16.       Innovation Fund R ound 2. (Lee C atlin, Assis tant C ounty Executive) 17.       Route 29 Solutions U pdate. (Mark Graham, Director of Community Development)   3:45 p.m. ­ A ction Items: 18.       Office of the C ommonwealth’s Attorney’s Funding Request. (D enise Lunsford, Commonwealth’s Attorney) 19.       Courts Projec t U pdate. (Bill Letteri, Deputy C ounty Executive)   20.       4:45 p.m. ­ Closed Meeting (2nd Floor conference room). 21.       Certify Closed Meeting. 22.       Boards and C ommissions:  a.         Board Member Committee Appointments. b.         Boards and Commiss ions  Vacancies  and Appointments.   23.        From the Public:  Matters Not Listed for Public Hearing on the Agenda.   6:00 p.m. ­ PU BLIC HEA RIN GS: 24.       To solicit public input on local community development and housing needs in relation to Community D evelopment Block Grant (CDBG) funding for potential projects  in the locality.  (R on White, Chief of H ousing) 25.       FY 15 Budget Amendment. (Lori Allshouse, Director, Office of Management and Budget) 26.       To receive comments on its intent to adopt an ordinance to amend County C ode Chapter 12, R egulated Enterprises, Article I, False Alarms, by amending Section 12­101, Definitions, to amend the definition of “false alarm” by  deleting “activity unauthorized by the alarm s ystem user or ac tivity outside the control of the alarm system user” from the list of alarms that do not constitute a false alarm and by adding “weather­ related events,” as  defined in the proposed ordinance, to the list of alarms that do not constitute a false alarm; by amending Section 12­102 to require that written notices issued to unregistered alarm system users be mailed to the physical addres s of the alarm us er and to reduce the service fee for third and subsequent responses to unregistered alarm s ystems from $300.00 to $150.00; by amending Section 12­104 to increase the amount of time an individual has to pay a fals e alarm service fee from thirty to ninety days and to eliminate the ass essment of a delinquent payment fee; and by amending Section 12­108 to eliminate the requirement that Police Department forms be used for appeals of false alarm notices and to increase the amount of time alarm system us ers have to submit appeals  from ten to thirty days.  (Greg J enk ins, Captain, Police Department)   27.       From the Board:  Committee Reports and Matters N ot Listed on the Agenda. 28.       From the County  Executive:  Report on Matters N ot Listed on the Agenda.   29.       Adjourn to January 13, 2015, 5:00 p.m., Auditorium.     CON SENT AGEND A      FOR A PPROVAL (action require):   13.1      Approval of Minutes: February  26, March 5, April 15, July 8 and October 30, 2014.   13.2      ACE Easement Purchases.   FOR IN FORMATION (no action required):   13.3      2014 Third Quarter C ertificate of Occupancy Report, as prepared by the Community Development Department.   13.4      2014 Third Quarter Building R eport, as prepared by the Community Development Department.   13.5      Copy of letter dated December 8, 2014, from Ronald L. Higgins , C hief of Zoning/Deputy Zoning Administrator, to Virginia Land Trust, c/o Greg Baldw in, re:  AMEND MENT TO OFFICIAL D ETER MINA TION OF PARCEL OF RECORD  – Tax Map 79, parcel 23C (noncontiguous portion) (Property of Virginia Land Trust) – Scottsville Magisterial District.   13.6      Copy of letter dated December 10, 2014, from Ronald L. Higgins, Chief of Zoning/Deputy Zoning Administrator, to Anvince Land Trust, c/o Sue A. Albrecht, Trus tee, re:  LOD201400015 ­ OFFIC IAL D ETER MINA TION OF DEVELOPMENT RIGHTS – Tax Map 61, Parcel 1B 1 (property of VDoT) – Jack Jouett Magisterial District.   13.7      Copy of letter dated December 11, 2014, from Sarah D. Baldwin, Senior Planner, to Cheryl Rudduck, re:  LOD 201400017 ­ OFFICIAL D ETER MINATION OF PARCEL OF RECORD  – Tax Map 119, Parcel 22  – Samuel Miller Magisterial District.   13.8      Virginia Department of Transportation, Culpeper D istrict, Albemarle County Monthly Report, J anuary 2015.     CLICK HE RE TO SIGN UP TO SPEAK AT PUBLIC HE ARINGS ONLY     Ret urn t o Top of   Agenda Ret urn t o Board of  Superv isors Home P age Ret urn t o Count y  Home Page